Loading...
2020-05-27 AgendaCHESTERFIELD COUNTY CHESTERFIELD, VIRGINIA 23832 AGENDA May 27, 2020 BOARD OF SUPERVISORS   LESLIE A.T. HALEY CHAIR MIDLOTHIAN DISTRICT KEVIN P. CARROLL VICE CHAIR MATOACA DISTRICT JIM A. INGLE BERMUDA DISTRICT CHRISTOPHER M. WINSLOW CLOVER HILL DISTRICT JAMES M. HOLLAND DALE DISTRICT JOSEPH P. CASEY, Ph.D. COUNTY ADMINISTRATOR 6:00 p.m. Evening Session ­ Virtual Meeting (Audio & Presentations)    1.Invocation      The Honorable Chris Winslow, Clover Hill District Supervisor    2.Pledge of Allegiance      Deputy County Administrator Scott Zaremba    3.Approval of Minutes     4.Requests to Postpone Agenda Items and Additions, Deletions or Changes in the Order of  Presentation     5.County Administration Update      A.Coronavirus and Economic Update      B.Other County Administration Updates     6.Board Member Reports     7.Resolutions and Special Recognitions      A.Recognition of Volunteer Contributions in Honor of Older Americans Month     8.New Business      A.Appointments      1.Community Policy and Management Team       2.John Tyler Community College Local Board      3.Camp Baker Management Board     Chesterfield County Board of Supervisors Meeting May 27, 2020  4.First Tee of Greater Richmond Board of Directors      5.Chesterfield County Airport Advisory Board      B.Consent Items      1.Adoption of Resolutions      a.Resolution Recognizing Firefighter Rotha A. Covington, Fire & EMS, Upon  Her Retirement      b.Resolution Recognizing Joy Kim Lester, Fire & EMS, Upon Her Retirement      c.Resolution Recognizing Captain David P. Schweiger, Fire & EMS, Upon His  Retirement      d.Resolution Recognizing Kevin L. Branch, Emergency Communications, Upon  His Retirement       e.Resolution Recognizing Mr. John P. Evans, Department of Utilities, Upon His  Retirement      f.Resolution Recognizing Ms. Patty Kluttz, Department of Mental Health   Support Services, Upon Her Retirement      g.Resolution Recognizing the 50th Anniversary of Lucy Corr      h.Resolution of Support for the Proposed Woolridge Road Extended Alignment      2.Real Property Requests      a.Acceptance of Parcels of Land      1.Acceptance of a Parcel of Land Along Woolridge Road and for  Grandin Avenue from Woolridge Development, LC       2.Acceptance of Parcels of Land Along Lucks Lane for Lucks Garden  Trail, Dogwood Grove Drive and Woodlet Meadow Lane from The  Grove at Lucks Lane LLC       3.Acceptance of Parcels of Land Along Woods Edge Road from the John  Watts Roberts Revocable Trust Dated March 14, 2012; Claremont  Associates, LLC; and Swarthmore College      4.Acceptance of Parcels of Land Along Woods Edge Road from  Swarthmore College      5.Approval of the Purchase of Land Along Reams Road for the Reams  Road Elementary School Replacement Project     Chesterfield County Board of Supervisors Meeting May 27, 2020  6.Acceptance of a Parcel of Land Along Harpers Mill Parkway from J.  Mark Sowers and Deborah K. Sowers      7.Acceptance of Four Parcels of Land Along Harpers Mill Parkway from  Douglas R. Sowers and Susan S. Sowers      8.Acceptance of a Parcel of Land Along Harpers Mill Parkway from  HMG Investments LLC      b.Conveyance of Easements       1.Designation of a Temporary Construction Easement and Conveyance  of a VDOT Utility Easement to the Commonwealth of Virginia for the  McRae Road and Rockaway Road Pedestrian Improvements Project      c.Requests to Quitclaim      1.Request to Quitclaim Portions of a 16’ Water Easement Across the  Property of Woodlands Real Estate, LLC      2.Request to Quitclaim Portions of a Drainage Easement (Private)      3.Confirmation of Approval of Process for Electronic Public Meetings      4.Subordination Agreement with Plantation Pipe Line Company and the Virginia  Department of Transportation      5.Set a Public Hearing to Consider the Abandonment of Portions of Omo Road, State  Road 739      6.Award of Construction Contract for Project #ADMN20000267, Route 360/Spring  Run Road Intersection Improvements      7.Award of Construction Contract for the Proctors Creek Wastewater Treatment Plant  Secondary Clarifiers 5 Through 8 Mechanism Replacement      8.Code Amendment Relative to Computer Controlled Variable Message Electronic  (EMC) Sign Resolution Standards (20PJ0113)      9.Code Amendment Relative to Computer Controlled Variable Message Electronic  (EMC) Sign and Communication Tower Zoning Fees (20PJ0116)       10.Amendment to PY2019/FY2020 Community Development Block Grant and HOME  Investment Partnerships Grant Annual Action Plan to incorporate CDBG­CV  funding/Appropriation of Funds      11.Acceptance of State Roads      12.Approval of Marketing/Consulting Services Contract for Revitalization of Jefferson  Davis Highway Corridor, Contract Number ADMN200000385     Chesterfield County Board of Supervisors Meeting May 27, 2020  13.Approval of Change Order Number One for Altairis Technology Partners Consulting  Contract       14.Modified Land Use Regulation During COVID­19 Emergency      15.Approval of Amended MOU with Dominion Relating to Transportation Plan in the  Vicinity of the Chesterfield Power Station      16.Approval of FY2021 Budget Amendments      17.Set Public Hearing Date to Consider Amending County Code Section 9­132 to  Increase the $10 Courthouse Security Fee to $20     9.Deferred Items     10.Requests for Manufactured Home Permits and Rezoning Placed on the Consent Agenda to be  Heard in the Following Order:  Withdrawals/Deferrals Cases Where the Applicant Accepts the Recommendation and There is No Opposition Cases Where the Applicant Does Not Accept the Recommendation and/or There is  Public Opposition Will Be Heard at Section 18     A.19SN0612 ­ Randolph's Pond LLC ­ Midlothian District      B.20SN0513 ­ Karina Fournier ­ Matoaca District      C.20SN0534 ­ Carthan F. Currin ­ Bermuda District      D.20SN0538 ­ Jennifer Elliot ­ Matoaca District      E.20SN0542 ­ Cross Tides Corporation ­ Dale District      F.20SN0543 ­ George C. Sheild ­ Clover Hill District      G.20SN0562 ­ Primax Properties, LLC ­ Bermuda District      H.20SN0563 ­ McDonald's Corporation ­ Midlothian District      I.20SN0565 ­ Jennifer A. and Kevin M. Kashurba ­ Matoaca District      J.20SN0573 ­ April J. Rice ­ Midlothian District      K.20SN0575 ­ Emerson­Roper Companies, LLC ­ Bermuda District      L.20SN0578 ­ Twin Rivers, LLC ­ Bermuda District     Chesterfield County Board of Supervisors Meeting May 27, 2020 11.Public Hearings      A.To Consider the FY2021­FY2026 Secondary Road Six­Year Plan and FY2021 Secondary  Road Budget      B.To Consider an Ordinance to Move the Polling Places for Five Forks Voting Precinct,  Winfree’s Store Voting Precinct, and Crestwood Voting Precinct       C.Consider the Exercise of Eminent Domain for the Acquisition of Permanent Water and  Temporary Construction Easements for the Harrowgate Road Water Line Improvements  Project      D.Conveyance of an Easement to Cellco Partnership d/b/a Verizon Wireless       E.Public Hearing to Consider Amendments to Section 9­51 of the County Code to Waive the  Imposition of Penalty on Delinquent Personal Property Tax Payments Due on June 5, 2020  until after July 31, 2020 and Adoption of an Emergency Ordinance to Waive the Accrual of  Interest on Such Payments until after July 31     12.Remaining Manufactured Home Permits and Zoning Requests     13.Citizen Comment Period on Unscheduled Matters (Via Online Comments)     14.Adjournment      A.Adjournment and Notice of Next Scheduled Meeting of the Board of Supervisors